CH CALORIFUGE CH CALORIFUGE

Active 5 Voie De L’arcade 10180 Saint-lye
Director
Cyril Serge Hautois
Gérant
Court Registry
TROYES
SIREN
522072016
SIRET (siège)
52207201600036
N° TVA
FR31522072016
Disclosure
Yes
Date of creation
01/05/2010
Financial year end
2023-04-30
Legal form
Share capital
N/C
Headcount
N/C
Form of practice
N/C
Code APE
43.29A
Business sector
N/C
Activity type
N/C

Premium Documents

Access all official documents and data exports with our Premium plan

Financial Analysis

Performance 2023 2022 2021 2020
Revenue - - - -
Gross margin - - - -
Gross operating surplus (EBITDA) - - - -
Operating income - - - -
Net income 2,8 k € -51 k € 5,5 k € -
Net margin rate (%) - - - -
Return on equity (%) - - - -
Return on assets - - - -
Profitability and productivity indicators 2023 2022 2021 2020
Value added - - - -
Value added / Revenue - - - -
Growth 2023 2022 2021 2020
Gross margin rate - - - -
EBITDA margin rate - - - -
Operating margin rate - - - -
Working Capital Management 2023 2022 2021 2020
Customer payment terms (days) - - - -
Supplier payment terms (days) - - - -
Self-financing capacity - - - -
Self-financing capacity / Revenue - - - -
Working capital 234 k € 260 k € 282 k € -
Working capital coverage 1,1 € 1,1 € 1,2 € -
Cash position 27 k € 33 k € 42 k € -
Financial debt 156 k € 193 k € 170 k € -
Repayment capacity - - - -
Debt ratio 1,1 € 1,5 € 0,8 € -
Financial autonomy 31 € 25 € 30 € -
Business structure 2023 2022 2021 2020
Debt coverage 0,5 € 0,8 € 1,5 € -
Wages and social charges - - - -
Business structure 2023 2022 2021 2020
Wages / Revenue - - - -

Directors Map

2 director(s)
Cyril Serge Hautois
Gérant
Since 2016-12-12
Born on 1973-09-04
Payns, FRANCE
Leo Jean-claude Serge Andre Hautois
Gérant
Since 2019-05-02
Born on 1999-06-10
Saint-Lyé, FRANCE

Beneficial Owners

0 beneficial owner(s)

No beneficial owners declared.

Establishments & Locations

3 establishment(s)
Headquarters Active
SIRET: 52207201600036
5 Voie De L’arcade 10180 Saint-lye
Created on 10/08/2017
43.29A -
Closed
SIRET: 52207201600028
30 Rue De Riancey 10180 Saint-lye
Created on 15/05/2013
43.29A -
Closed
SIRET: 52207201600010
1 Rue Du Bois 10180 Saint-lye
Created on 01/05/2010
43.29A -

Annual Accounts

7 fiscal year(s)
CH CALORIFUGE
Confidential results
Closing : 30/04/2023
Filing : 01/12/2023
Type : CS
CH CALORIFUGE
Confidential results
Closing : 30/04/2022
Filing : 03/11/2022
Type : CS
CH CALORIFUGE
Confidential results
Closing : 30/04/2021
Filing : 02/05/2022
Type : CS
CH CALORIFUGE
Confidential
Closing : 30/04/2020
Filing : 29/10/2020
Type : CS
CH CALORIFUGE
Confidential
Closing : 30/04/2019
Filing : 21/02/2020
Type : CS
CH CALORIFUGE
Confidential
Closing : 30/04/2018
Filing : 27/11/2018
Type : CS
CH CALORIFUGE
Confidential
Closing : 30/04/2017
Filing : 08/09/2017
Type : CS

Published Deeds

22 document(s)
23/05/2022
Attestation
Démission(s) de gérant(s)
23/05/2022
Attestation
Démission(s) de gérant(s)
23/05/2022
Attestation
Démission(s) de gérant(s)
23/05/2022
Attestation
Démission(s) de gérant(s)
02/05/2019
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
02/05/2019
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
29/08/2017
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
TRANSFERT DU SIEGE ET PRINCIPAL AU 5 VOIE E L'ARCADE 10180 ST LYE
29/08/2017
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
TRANSFERT DU SIEGE ET PRINCIPAL AU 5 VOIE E L'ARCADE 10180 ST LYE
08/03/2016
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Extension de l'objet social
Nomination(s) de gérant(s)
Adjonction d'activité(s)
08/03/2016
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Extension de l'objet social
Nomination(s) de gérant(s)
Adjonction d'activité(s)
08/03/2016
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Extension de l'objet social
Nomination(s) de gérant(s)
Adjonction d'activité(s)
08/03/2016
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Extension de l'objet social
Nomination(s) de gérant(s)
Adjonction d'activité(s)
08/03/2016
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Extension de l'objet social
Nomination(s) de gérant(s)
Adjonction d'activité(s)
08/03/2016
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Extension de l'objet social
Nomination(s) de gérant(s)
Adjonction d'activité(s)
24/06/2013
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
TRANSFERT AU 30 RUE DE RIANCEY 10180 SAINT LYE
24/06/2013
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
TRANSFERT AU 30 RUE DE RIANCEY 10180 SAINT LYE
02/12/2010
Procès-verbal d'assemblée
Changement relatif à l'activité
02/12/2010
Procès-verbal d'assemblée
Changement relatif à l'activité
02/12/2010
Procès-verbal d'assemblée
Changement relatif à l'activité
02/12/2010
Procès-verbal d'assemblée
Changement relatif à l'activité
28/04/2010
Acte sous seing privé
Constitution
28/04/2010
Acte sous seing privé
Constitution

BODACC Announcements

22 announcement(s)
09/09/2025
Procédures collectives
View announcement
28/01/2025
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
View announcement
05/12/2023
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
View announcement
06/11/2022
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
View announcement
25/05/2022
Modifications diverses
Modification survenue sur l'administration.
View announcement
04/05/2022
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
View announcement
31/10/2020
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
View announcement
25/02/2020
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
View announcement
05/05/2019
Modifications diverses
Modification survenue sur l'administration.
View announcement
06/12/2018
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
View announcement
16/09/2017
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
View announcement
03/09/2017
Modifications diverses
Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
View announcement
04/01/2017
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
View announcement
22/03/2016
Modifications diverses
Modification survenue sur l'activité, l'administration
View announcement
19/11/2015
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
View announcement
13/12/2014
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
View announcement
10/01/2014
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
View announcement
04/07/2013
Modifications diverses
Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
View announcement
25/10/2012
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
View announcement
27/01/2012
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
View announcement
17/12/2010
Modifications diverses
Modification survenue sur l'activité
View announcement
19/05/2010
Créations
View announcement

Registered Trademarks

0 trademark(s)

No trademarks registered by this company

Financial Diagnostics

Premium
SME Score
Financial Performance Index

Financial health assessment based on the company's profitability, solvency, and robustness.

Profitability
--
Solvency
--
Robustness
--
FPI Score
--
AFDCC Score
Credit Risk Assessment

Credit risk score established by the French Association of Credit Managers to assess financial reliability.

AFDCC Score
--
Risk Level: --
Balance Sheet Type
--
Fiscal Year
--

Scores are calculated from balance sheets filed with the commercial courts. Data provided by DataInfogreffe.

ClickEntreprise Premium

Access all company data

Premium Plan
49,90 /month excl. VAT
  • 30 documents / month
  • Dedicated customer support
  • Financial Analysis CSV
  • Director data
  • Favorite companies
  • Registered Trademarks
  • Legal history BODACC
  • Financial scoring
🎁 48h trial 1,90€ only
Then 49,90€/month · Cancel freely
Start Premium trial

Secure payment • Cancel freely